UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Midmarch Limited

Adresse
2 Nuffield Road
Nuffield Industrial Estate
Poole
BH17 0RB
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 05082778 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussunaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)74990 Non-trading company
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Morris Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Companies House Nummer: 13197092 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Handley, Adrian Francis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Handley, Emma Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Kemp, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Kemp, Raymond John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 04.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Bucknell, Jeremy Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bursey, Sam Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hobson, Daniel Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Cco Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sackett, Darryl Nuffield Industrial Estate, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Seeley, Debbie Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bolger, Daniel Nuffield Industrial Estate, Poole, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Htun-Kay, Michelle Nuffield Industrial Estate, Poole, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American
    Matthews, Sean Nuffield Industrial Estate, Poole, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Neilson, Gregory John Nuffield Industrial Estate, Poole, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag D S Callards Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02825085 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors