UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Innovus Company Secretaries Limited

Adresse
Queensway House
11 Queensway
New Milton
BH25 5NR
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 05988785 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)82190 - Copy-Shops; Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Fairfield Company Secretaries Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Innovus Business Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Company Registration: 14769299 (England) Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chamonix Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 05856372 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chamonix Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2023 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 12500321 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Chamonix Group Ltd The Lantern, 75 Hampstead Road, London, England, NW1 2PL Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2006 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05856372
    Chamonix Group Ltd, Queensway House 11 Queensway, New Milton, United Kingdom, BH25 5NR Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Perrett, Steve John 75 Hampstead Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Saleh, Ouda 75 Hampstead Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Austin, Louise Catherine Hyde Hall Farm, Sandon Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2008 Löschung: 02.12.2020 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Chamonix Group Ltd Hyde Hall Farm, Sandon, Buntingford, United Kingdom, SG9 0RU Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2006 Löschung: 01.04.2016 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 05856372
    Howell, Nigel, Mr. New Milton, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2020 Löschung: 18.08.2022 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Keenan, John Joseph New Milton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2024 Löschung: 01.10.2025 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mitchell, Lavinia Ruth Hyde Hall Farm, Sandon Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2008 Löschung: 29.07.2016 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Povey, Adrian Martin Standon, Ware Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2008 Löschung: 10.07.2015 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    West, John Edward Station Road, Much Hadham Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2006 Löschung: 04.09.2008 Rolle: Director Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Handley Gardens (Lancaster Avenue) Block Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Companies House Nummer: 14068694 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB CE Oakfield Gardens Hyde Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.07.2017 Companies House Nummer: 06406964 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB CE Poppy Fields (Benwick) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 06353915 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cottonfields, Gibfield Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2016 Löschung: 27.09.2017 Companies House Nummer: 10375713 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Greenwood Meadows (Harwell) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.07.2018 Companies House Nummer: 09127543 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Hinckley Park Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.08.2017 Companies House Nummer: 08179239 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Serpentine Walk Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.07.2018 Companies House Nummer: 06968648 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Sovereign Fields (Bracknell H9) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2017 Companies House Nummer: 07326161 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB The Limes (Lindfield) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.06.2017 Companies House Nummer: 07300430 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Woodford Grange Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2016 Löschung: 27.09.2017 Companies House Nummer: 10375641 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more