UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Alycidon Capital LTD

Adresse
19 Highfield Road
Edgbaston
Birmingham
B15 3BH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
10. Mai 2016
FB Name Alycidon Capital Limited
Firmenbuch-Nummer 07875945 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren
28131 - Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House
Eales, Darryl Charles Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2016 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Tompsett, Rodney Graham Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2016 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Eales, Darryl Charles Edgbaston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2011 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Tompsett, Rodney Graham Edgbaston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2015 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ward, Michael James Birmingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2011 Löschung: 12.12.2011 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag Advanced Interactive Materials S Cience LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2017 Companies House Nummer: 07934090 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Advanced Interactive Materials Science LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2017 Companies House Nummer: 07934090 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Alycidon Capital TWO Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2016 Companies House Nummer: 08767399 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB CAS 2012 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Companies House Nummer: 03533876 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag COX Wokingham Plastics Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Companies House Nummer: 02959737 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Process Systems International LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2017 Companies House Nummer: 02689358 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Promold International LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Companies House Nummer: 05156951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Sagittite Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2017 Companies House Nummer: 10187772 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Instrumentel Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.02.2017 Companies House Nummer: 04325633 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors