UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

The Beaumont Hotel Limited

Adresse
157-160 Piccadilly
London
W1J 9EB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
24. Dezember 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
4. Juli 2019
FB Adresse 8 Balderton Street Brown Hart Gardens
London
W1K 6TF
Firmenbuch-Nummer 08031843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • The Beaumont Hotel Property Limited
  • Beaumont Propco Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Beaumont Hotel (Midco) Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2018 Companies House Nummer: 11637599 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Barclay, Aidan Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2018 Löschung: 23.11.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Corbin & King Hotel Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2016 Löschung: 27.09.2018 Companies House Nummer: 04739085 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Corbin & King Restaurant Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.09.2016 Companies House Nummer: 07887202 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Changizi, Gheeve Richard Mayfair, London Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Faber, Richard Julian Robert Mayfair, London Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Harrison, Paul James Mayfair, London Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British
    Heard, William John Mayfair, London Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Palmer, Duncan Roderick Brown Hart Gardens, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2021 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Soames, Arthur Nicholas Winston Mayfair, London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 02.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British