UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Chesterton Global LTD

Adresse
40 Connaught Street
London
W2 2AB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
21. Mai 2021
FB Name Chesterton UK Services Limited
Firmenbuch-Nummer 05334580 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Chesterson Global Limited | Chesterton Humberts
  • Chesterson Global Limited
  • Intercede 2013 Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Campions Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Companies House Nummer: 14763280 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Mussa, Salaheddin Mohamad Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2016 Löschung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Taher, Reem Abdelkarim Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2021 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Ennis, John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2022 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English
    Keenan, John Joseph Hyde Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mercantile Group Limited, 34 Rue De L'Athenee, Geneva 12, Switzerland, Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Rolle: Director
    Saleh, Ouda Hyde Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Collins, Allan Hyde Park, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2013 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Davies, Richard George Hyde Park, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Head Of Residential Lettings Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ennis, John Alexander London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2022 Löschung: 23.10.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Malia, Sami Roumi London, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2020 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian
    Mercantile Group Limited Rue De L'Athenee, Geneva 12, Switzerland, Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 23.10.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 00166349
    Mussa, Mohamed Salaheddin Mohamed Hyde Park, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2021 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 03.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Palmer, Michael Hyde Park, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2022 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

    gb-flag Ascot Mr LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2019 Companies House Nummer: 09775965 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Chesterton Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05391455 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Copping Joyce Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03502707 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Lrsl AST Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Companies House Nummer: 13244237 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Owen Commercial Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Companies House Nummer: 05888090 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Owen Commercial Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Companies House Nummer: 05888090 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Universal Management Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2023 Companies House Nummer: 01513268 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Springtide Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.10.2023 Companies House Nummer: 02197281 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%