UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Apsley Developments LTD

Adresse
Chells Manor Lodge
2 Manor House Drive
Stevenage
SG2 7RR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
29. Oktober 2022
FB Name Apsley Developments Limited
Firmenbuch-Nummer 03326072 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House
James, John Hilton Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 08.1945 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • James, Jonathan Anthony Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • James, Richard John Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • James, Timothy Michael Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • gb-flag GB James Family Trust 2019 Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2020 Löschung: 20.02.2020 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Significant influence or control as trust
  • gb-flag GB Marchfield Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2020 Companies House Nummer: 06382447 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Campbell, Ann Rosemary Oxford, Oxfordshire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2009 Geburtsdatum: 12.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Denmead, Barry Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.1997 Geburtsdatum: 06.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    James, John Hilton Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.1997 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    James, Richard John Harpenden, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2002 Geburtsdatum: 08.1971 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    James, Richard John Harpenden, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.1997 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Land Negotiator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Parker, Robert Leslie Pirton, Hitchin, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.1997 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Percy, Charles Richard Flaunden Lane Bovingdon, Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.1997 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British